My family research project.

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 51 til 100 fra 494

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
51 Bidwell, Electa  28 nov. 1792Connecticut, USA I70867 AALT 
52 Bidwell, Ella M.  7 sep. 1850Connecticut, USA I67264 AALT 
53 Bidwell, Erastus Frank  13 dec. 1816Connecticut, USA I67058 AALT 
54 Bidwell, Florence C.  11 jun. 1852Connecticut, USA I67226 AALT 
55 Bidwell, Grove Sherman  1873Connecticut, USA I67343 AALT 
56 Bidwell, Harriett  ml. 1851 og 1852Connecticut, USA I69661 AALT 
57 Bidwell, Huldah  1779Connecticut, USA I7754 AALT 
58 Bidwell, Lena Belle  jun. 1891Connecticut, USA I66901 AALT 
59 Bidwell, Martin C.  1857Connecticut, USA I67125 AALT 
60 Bidwell, Maryett  1855Connecticut, USA I67395 AALT 
61 Bidwell, Nathan C.  1855Connecticut, USA I66843 AALT 
62 Bidwell, Mrs Rhoda  1824Connecticut, USA I66887 AALT 
63 Bidwell, Ruhama  1737Connecticut, USA I59571 AALT 
64 Bidwell, Ruth Wagner  18 sep. 1908Connecticut, USA I67402 AALT 
65 Bidwell, Sarah A.  23 maj 1845Connecticut, USA I67238 AALT 
66 Bidwell, Thomas Clayton  2 jun. 1841Connecticut, USA I67040 AALT 
67 Bierce, Martha  1766Connecticut, USA I98915 AALT 
68 Birge, Louise M  1 apr. 1882Connecticut, USA I65403 AALT 
69 Bitgood, Frederick Ellsworth  2 jul. 1861Connecticut, USA I96107 AALT 
70 Bitgood, Mary Josephine  14 jun. 1886Connecticut, USA I84609 AALT 
71 Bitgood, Rose Evelyn  1896Connecticut, USA I84546 AALT 
72 Bixby, Chloe  ca. 1771Connecticut, USA I38087 AALT 
73 Bixby, William Lewis  1835Connecticut, USA I38080 AALT 
74 Blakeslee, Joseph  1730Connecticut, USA I1698 AALT 
75 Brace, Edmund  1811Connecticut, USA I41632 AALT 
76 Bragg, Alzade Elizabeth  okt. 1845Connecticut, USA I57215 AALT 
77 Brainard, Mary Louise  23 mar. 1908Connecticut, USA I63523 AALT 
78 Brewster, Alexander  1775Connecticut, USA I15404 AALT 
79 Brewster, John  1773Connecticut, USA I15386 AALT 
80 Brewster, Judah  27 feb. 1729Connecticut, USA I13014 AALT 
81 Brewster, Mary  22 okt. 1796Connecticut, USA I134876 AALT 
82 Brewster, Paul  1769Connecticut, USA I57091 AALT 
83 Brewster, Rebecca  ca. 1784Connecticut, USA I136338 AALT 
84 Brewster, Ruth  14 jul. 1893Connecticut, USA I136309 AALT 
85 Brewster, Sally  1799Connecticut, USA I14055 AALT 
86 Brewster, Truelove  16 maj 1725Connecticut, USA I135738 AALT 
87 Brigham, Barbara L  nov. 1888Connecticut, USA I40190 AALT 
88 Bristol, Sarah Elizabeth  1904Connecticut, USA I67215 AALT 
89 Brockett, Isaac  1747Connecticut, USA I62856 AALT 
90 Brown, Allyn M  1910Connecticut, USA I65622 AALT 
91 Brown, Rusel  1774Connecticut, USA I16752 AALT 
92 Buckland, Thomas  1650Connecticut, USA I127104 AALT 
93 Bunnell, Hezekiah  23 nov. 1681Connecticut, USA I39256 AALT 
94 Burdick, Hattie E.  1862Connecticut, USA I29365 AALT 
95 Burdick, Martin  1835Connecticut, USA I29389 AALT 
96 Buren, Myron Van  5 jul. 1898Connecticut, USA I71903 AALT 
97 Burnham, David  1700Connecticut, USA I27109 AALT 
98 Burnham, Philip Theodore  1885Connecticut, USA I66771 AALT 
99 Burnham, William Wallace  14 apr. 1828Connecticut, USA I73295 AALT 
100 Butler, Lydia  1780Connecticut, USA I38664 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Næste»



Død

Match 51 til 100 fra 276

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
51 Brewster, William Mansfield  Connecticut, USA I12917 AALT 
52 Bridwell, John  1763Connecticut, USA I27180 AALT 
53 Brown, Katurah  20 mar. 1766Connecticut, USA I27144 AALT 
54 Buell, Sarah  4 okt. 1734Connecticut, USA I48658 AALT 
55 Burnham, Eleanor  8 apr. 1780Connecticut, USA I46236 AALT 
56 Burnham, Giles Geles  2 okt. 1858Connecticut, USA I46181 AALT 
57 Burrows, John Baldwin  3 mar. 1848Connecticut, USA I128372 AALT 
58 Carrington, Anna  Connecticut, USA I63004 AALT 
59 Cartwright, Nicholas  24 maj 1782Connecticut, USA I72374 AALT 
60 Cary, Phineas  1824Connecticut, USA I13843 AALT 
61 Chapman, Benjamin  15 dec. 1760Connecticut, USA I357 AALT 
62 Chapman, Samuel  Connecticut, USA I170 AALT 
63 Chapman, Temperance  Connecticut, USA I367 AALT 
64 Chesebrough, Priscilla  1780Connecticut, USA I117693 AALT 
65 Chesebrough, Prudence  29 aug. 1809Connecticut, USA I117678 AALT 
66 Chipman, Thomas  28 mar. 1795Connecticut, USA I124913 AALT 
67 Coats, Mary  Connecticut, USA I1463 AALT 
68 Coleman, Joseph  1835Connecticut, USA I60803 AALT 
69 Coles, Joan  Connecticut, USA I18238 AALT 
70 Couch, Hannah  1704Connecticut, USA I112263 AALT 
71 Couch, Mary  1729Connecticut, USA I112266 AALT 
72 Crary, Evelina  1879Connecticut, USA I81017 AALT 
73 Crawford, Elizabeth  1869Connecticut, USA I91061 AALT 
74 Crocker, Mary  1825Connecticut, USA I61329 AALT 
75 Crocker, Sarah  Connecticut, USA I6244 AALT 
76 Cummins, Stephen  1798Connecticut, USA I29111 AALT 
77 De Cordova Y Benavides, Maria Joaquina Fernandez  1825Connecticut, USA I118476 AALT 
78 Denison, Samuel  10 mar. 1792Connecticut, USA I22162 AALT 
79 Denison, Sarah  1800Connecticut, USA I26972 AALT 
80 Dewolf, Azubah  1800Connecticut, USA I39378 AALT 
81 Dodd, Edward  1729Connecticut, USA I26983 AALT 
82 Dodge, John  aug. 1775Connecticut, USA I71835 AALT 
83 Drake, David  1790Connecticut, USA I103117 AALT 
84 Drake, Job  3 apr. 1790Connecticut, USA I107397 AALT 
85 Drake, Lydia  7 maj 1702Connecticut, USA I57527 AALT 
86 Dunbar, Joseph  1730Connecticut, USA I74052 AALT 
87 Durkee, Jeremiah  30 jan. 1734Connecticut, USA I43796 AALT 
88 Edwards, Sarah Anne  1662Connecticut, USA I20567 AALT 
89 Elliot, Mary  9 mar. 1771Connecticut, USA I143811 AALT 
90 Ellsworth, John  1760Connecticut, USA I108144 AALT 
91 Ellsworth, Capt. John  14 jul. 1779Connecticut, USA I11303 AALT 
92 Elwell, Angeline  9 maj 1914Connecticut, USA I10700 AALT 
93 Elwell, Deborah  Connecticut, USA I124432 AALT 
94 Elwell, Esther  Connecticut, USA I32 AALT 
95 Elwell, Grissel  6 jun. 1816Connecticut, USA I261 AALT 
96 Elwell, Isaac  1799Connecticut, USA I391 AALT 
97 Elwell, Mary  Connecticut, USA I440 AALT 
98 Estabrook, Capt Joseph  AfdødConnecticut, USA I11937 AALT 
99 Everett, Hannah  3 aug. 1826Connecticut, USA I79102 AALT 
100 Fenton, Augusta T  23 mar. 1855Connecticut, USA I115870 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»



Begravet

Match 51 til 84 fra 84

«Forrige 1 2

   Efternavn, Fornavn    Begravet    Person-ID   Træ 
51 Marvin, Martha  Connecticut, USA I126248 AALT 
52 Meach, Moses  Connecticut, USA I27221 AALT 
53 Metcalfe, Simeon  Connecticut, USA I26966 AALT 
54 Morgan, Daniel  Connecticut, USA I135785 AALT 
55 Morgan, George W  1865Connecticut, USA I135810 AALT 
56 Morgan, John Jr.  Connecticut, USA I136328 AALT 
57 Morgan, John Jr.  Connecticut, USA I27224 AALT 
58 Morgan, Sarah  Connecticut, USA I134337 AALT 
59 North, Hannah  Connecticut, USA I29702 AALT 
60 Noyes, James Jr.  1718Connecticut, USA I35330 AALT 
61 Parke, Hezekiah  feb. 1752Connecticut, USA I24977 AALT 
62 Parmalee, Charles Ives  Connecticut, USA I62578 AALT 
63 Parmalee, Mildred Ives  Connecticut, USA I62899 AALT 
64 Pease, John  jun. 1761Connecticut, USA I86584 AALT 
65 Pease, John  jun. 1761Connecticut, USA I86334 AALT 
66 Phelps, Captain Samuel  okt. 1741Connecticut, USA I103455 AALT 
67 Pratt, Elisabeth  Connecticut, USA I94584 AALT 
68 Pratt, Hepsibah  Connecticut, USA I94594 AALT 
69 Preston, Esther  Connecticut, USA I87032 AALT 
70 Sanford, Robert  Connecticut, USA I60449 AALT 
71 Sanford, Susan Alice  Connecticut, USA I64065 AALT 
72 Shepard, Isaac  Connecticut, USA I117719 AALT 
73 Simmons, Abigail  Connecticut, USA I10633 AALT 
74 Spencer, Elizabeth  Connecticut, USA I126813 AALT 
75 Spencer, Roswell  1806Connecticut, USA I27012 AALT 
76 Storrs, Hannah  Connecticut, USA I52043 AALT 
77 Tanner, Joseph  Connecticut, USA I27287 AALT 
78 Tanner, Susan Mercelia  Connecticut, USA I13600 AALT 
79 Tarbox, Sarah  aug. 1754Connecticut, USA I29453 AALT 
80 Timmerman, William Orton  Connecticut, USA I66058 AALT 
81 Tudor, Mary  Connecticut, USA I13422 AALT 
82 Whitmore, Elizabeth  Connecticut, USA I94664 AALT 
83 Whittemore, Alvan Fosdick  Connecticut, USA I94556 AALT 
84 Woodruff, Philo  Connecticut, USA I35251 AALT 

«Forrige 1 2



Gift

Match 51 til 100 fra 101

«Forrige 1 2 3 Næste»

   Familie    Gift    Familie-ID   Træ 
51 Judd / Hudson  1931Connecticut, USA F13033 AALT 
52 Judd / Marvin  1925Connecticut, USA F13032 AALT 
53 Judd / Welles  25 apr. 1855Connecticut, USA F13054 AALT 
54 Kellogg / Phelps  1766Connecticut, USA F24022 AALT 
55 Kelsey / Gladwin  1908Connecticut, USA F14540 AALT 
56 Kirtland / Benham  4 jul. 1829Connecticut, USA F12065 AALT 
57 Kirtland / Carrington  22 feb. 1819Connecticut, USA F12237 AALT 
58 Kirtland / Stannard  1846Connecticut, USA F12289 AALT 
59 Lane / Carrington  jul. 1855Connecticut, USA F12101 AALT 
60 Loomis / Brewster  mar. 1806Connecticut, USA F30138 AALT 
61 Loomis / Cook  eft. 1691Connecticut, USA F11554 AALT 
62 Lovegrove / Fillmore  1775Connecticut, USA F6534 AALT 
63 Lyon / Page  6 maj 1848Connecticut, USA F30162 AALT 
64 Merriam / Parker  1798Connecticut, USA F6762 AALT 
65 Mix / Goodwin  1747Connecticut, USA F15033 AALT 
66 Monson / Todd  11 nov. 1868Connecticut, USA F11811 AALT 
67 Moore / Pember  1867Connecticut, USA F13147 AALT 
68 Moulthrop / Way  22 jun. 1745Connecticut, USA F284 AALT 
69 Paine / Ellsworth  1769Connecticut, USA F3899 AALT 
70 Phelps / Denison  10 sep. 1757Connecticut, USA F16033 AALT 
71 Phelps / Randall  30 nov. 1648Connecticut, USA F26639 AALT 
72 Phelps / Wilson  4 jun. 1646Connecticut, USA F21042 AALT 
73 Porter / Snow  26 dec. 1728Connecticut, USA F1242 AALT 
74 Root / Hemingway  1816Connecticut, USA F2255 AALT 
75 Rudd / Lathrop  1772Connecticut, USA F3705 AALT 
76 Sedgwick / Ensign  17 okt. 1825Connecticut, USA F11915 AALT 
77 Sedgwick / Merriam  8 maj 1819Connecticut, USA F11868 AALT 
78 Sedgwick / Tyler  1744Connecticut, USA F12021 AALT 
79 Sedgwick / Webster Mix  jun. 1820Connecticut, USA F12718 AALT 
80 Seymour / Hoadley  17 sep. 1836Connecticut, USA F30565 AALT 
81 Shepard / Angell  1817Connecticut, USA F6003 AALT 
82 Smith / Burrows  6 mar. 1788Connecticut, USA F7446 AALT 
83 Spencer / Booth  28 feb. 1699Connecticut, USA F4009 AALT 
84 Spencer / Clark  1730Connecticut, USA F4734 AALT 
85 Stanton / Dennison  16 jun. 1680Connecticut, USA F8615 AALT 
86 Stanton / Palmer  ca. 1778Connecticut, USA F2120 AALT 
87 Stevens / Hodges  5 dec. 1742Connecticut, USA F330 AALT 
88 Stevens / Peck  1714Connecticut, USA F229 AALT 
89 Story / Brainard  14 apr. 1928Connecticut, USA F12287 AALT 
90 Stoughton / Ellsworth  1769Connecticut, USA F10588 AALT 
91 Tanner / Campbell  17 okt. 1857Connecticut, USA F4733 AALT 
92 Terry / Sanford  2 sep. 1865Connecticut, USA F12485 AALT 
93 Thompson / Lathrop  1683Connecticut, USA F15965 AALT 
94 Tuttle / Beecher  1834Connecticut, USA F17020 AALT 
95 Tuttle / Beecher  1847Connecticut, USA F12182 AALT 
96 Wadsworth / Isham  22 okt. 1825Connecticut, USA F753 AAP 
97 Weeks / Armstrong  1726Connecticut, USA F3909 AALT 
98 Woodruff / Mason  3 dec. 1730Connecticut, USA F16348 AALT 
99 Yale / Andrews  31 jul. 1907Connecticut, USA F12249 AALT 
100 Yale / Kirtland  23 jul. 1822Connecticut, USA F14260 AALT 

«Forrige 1 2 3 Næste»



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af John Lynge.