Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 151 til 200 fra 494

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
151 Wadsworth, Jared  1776Connecticut, USA I3147 AAP 
152 Wood, Mrs. Sophia  1776Connecticut, USA I2870 AAP 
153 Lathrop, Mary Polly  9 jan. 1776Connecticut, USA I74544 AALT 
154 Hinckley, Henry  1777Connecticut, USA I95613 AALT 
155 Markham, William  1777Connecticut, USA I31646 AALT 
156 Strong, Jonathan  1777Connecticut, USA I16446 AALT 
157 Markham, Daniel  1778Connecticut, USA I31635 AALT 
158 Spencer, Catherine  1778Connecticut, USA I11394 AALT 
159 Wightman, Sarah  2 jan. 1778Connecticut, USA I125925 AALT 
160 Palmer, Chloe  13 nov. 1778Connecticut, USA I125667 AALT 
161 Smith, Nathaniel Roswell  24 nov. 1778Connecticut, USA I61018 AALT 
162 Bidwell, Huldah  1779Connecticut, USA I7754 AALT 
163 Hinckley, Polly  1779Connecticut, USA I95471 AALT 
164 Strong, Mary  1779Connecticut, USA I13029 AALT 
165 Smith, Sally Denison  28 aug. 1779Connecticut, USA I35812 AALT 
166 Adgate, Luther  1780Connecticut, USA I43806 AALT 
167 Badcock, Mary Ann  1780Connecticut, USA I77881 AALT 
168 Butler, Lydia  1780Connecticut, USA I38664 AALT 
169 De Wolf, William  1780Connecticut, USA I14794 AALT 
170 Stiles, Jonathan  11 aug. 1780Connecticut, USA I9422 AALT 
171 Spencer, Mary  11 okt. 1780Connecticut, USA I12824 AALT 
172 Adsell, Ruth H  1781Connecticut, USA I48874 AALT 
173 Hinckley, Patty  1781Connecticut, USA I95583 AALT 
174 Wood, Rhoda  26 jan. 1781Connecticut, USA I2869 AAP 
175 Gardner, Francis J. Sr.  1782Connecticut, USA I58340 AALT 
176 Johnston, Elizabeth  1782Connecticut, USA I10333 AALT 
177 Lamphere, S  ca. 1782Connecticut, USA I39744 AALT 
178 Stiles, Patty  1782Connecticut, USA I9454 AALT 
179 Potter, Joel  9 aug. 1782Connecticut, USA I2880 AAP 
180 Coleman, Joseph  1783Connecticut, USA I60803 AALT 
181 Crandall, Jemima  ca. 1783Connecticut, USA I39292 AALT 
182 Hinckley, Charlotte  1783Connecticut, USA I95641 AALT 
183 Pember, Jabez  1783Connecticut, USA I14641 AALT 
184 Brewster, Rebecca  ca. 1784Connecticut, USA I136338 AALT 
185 Judd, Chester S  1784Connecticut, USA I99077 AALT 
186 Keith, Roswell  1784Connecticut, USA I43546 AALT 
187 Pember, Willys  1784Connecticut, USA I14691 AALT 
188 Spencer, Hannah  1784Connecticut, USA I12747 AALT 
189 Barnes, Selah  1785Connecticut, USA I2742 AAP 
190 Hinckley, Sallie  1785Connecticut, USA I95575 AALT 
191 Smith, Lucretia  1786Connecticut, USA I23757 AALT 
192 Hull, Harriet  11 jan. 1786Connecticut, USA I117604 AALT 
193 Philo, Elizabeth  1787Connecticut, USA I25687 AALT 
194 Gurnsey, Samantha  nov. 1787Connecticut, USA I94639 AALT 
195 Potter, Daniel Woodruff  19 dec. 1787Connecticut, USA I30710 AALT 
196 Potter, Merilla  19 dec. 1787Connecticut, USA I28308 AALT 
197 Johnston, Enos  1788Connecticut, USA I10426 AALT 
198 Philo, Asahel  1789Connecticut, USA I12304 AALT 
199 Miles, Mary  1 mar. 1789Connecticut, USA I13572 AALT 
200 Baker, Elizabeth B.  jul. 1789Connecticut, USA I52699 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Næste»



Død

Match 151 til 200 fra 276

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
151 Perkins, John  1800Connecticut, USA I23673 AALT 
152 Seymour, Ira  1800Connecticut, USA I70839 AALT 
153 Benjamin, Johnathan  jul. 1800Connecticut, USA I12723 AALT 
154 Perkins, Polydore  19 nov. 1800Connecticut, USA I4461 AALT 
155 Woodward, Hannah  1801Connecticut, USA I9196 AALT 
156 Kingsbury, Irena  13 feb. 1803Connecticut, USA I55730 AALT 
157 Chesebrough, Prudence  29 aug. 1809Connecticut, USA I117678 AALT 
158 Lord, Mehitabel  1810Connecticut, USA I61190 AALT 
159 Smith, Oliver  17 dec. 1810Connecticut, USA I35753 AALT 
160 Paine, Ezra  27 okt. 1811Connecticut, USA I25554 AALT 
161 Spencer, Elizabeth  4 feb. 1812Connecticut, USA I12661 AALT 
162 Hosmer, Ashbel  2 apr. 1812Connecticut, USA I79257 AALT 
163 Arnold, Rhodes  22 jun. 1812Connecticut, USA I74950 AALT 
164 Loomis, Hannah  1815Connecticut, USA I5441 AALT 
165 Knapp, Charity  jan. 1815Connecticut, USA I4928 AALT 
166 Elwell, Grissel  6 jun. 1816Connecticut, USA I261 AALT 
167 Barden, Sarah  28 feb. 1818Connecticut, USA I73276 AALT 
168 Matson, Amy  1820Connecticut, USA I11475 AALT 
169 Loomis, Ursalah  3 nov. 1820Connecticut, USA I11346 AALT 
170 Frink, Eunice  30 nov. 1820Connecticut, USA I43673 AALT 
171 Adams, Lois  21 maj 1821Connecticut, USA I11013 AALT 
172 Adams, William  21 maj 1821Connecticut, USA I11122 AALT 
173 Haven Hemenway, Elizabeth  22 nov. 1821Connecticut, USA I136339 AALT 
174 Linsly, Ebenezer  8 nov. 1822Connecticut, USA I21252 AALT 
175 Cary, Phineas  1824Connecticut, USA I13843 AALT 
176 Hubbard, Aaron  ca. 1824Connecticut, USA I94634 AALT 
177 Williams, Edward  5 jun. 1824Connecticut, USA I75283 AALT 
178 Atwater, Hannah  1825Connecticut, USA I51273 AALT 
179 Crocker, Mary  1825Connecticut, USA I61329 AALT 
180 De Cordova Y Benavides, Maria Joaquina Fernandez  1825Connecticut, USA I118476 AALT 
181 Hubbard, Edmund  1825Connecticut, USA I94612 AALT 
182 Ward, Rebecca  2 apr. 1825Connecticut, USA I42484 AALT 
183 Graves, Elder Josiah  24 jul. 1825Connecticut, USA I87110 AALT 
184 Hooker, Samuel  6 aug. 1825Connecticut, USA I143659 AALT 
185 Mack, Sarah  mar. 1826Connecticut, USA I104277 AALT 
186 Judd, Mercy  27 apr. 1826Connecticut, USA I9048 AALT 
187 Everett, Hannah  3 aug. 1826Connecticut, USA I79102 AALT 
188 Seymour  1827Connecticut, USA I65635 AALT 
189 Phelps, Sarah  30 nov. 1827Connecticut, USA I62257 AALT 
190 Wilcox, Stephen  15 apr. 1828Connecticut, USA I117897 AALT 
191 Stowell, Sarah  1829Connecticut, USA I93843 AALT 
192 Stanton, Cynthia L  15 jan. 1829Connecticut, USA I43963 AALT 
193 Beckwith, Thomas  22 okt. 1829Connecticut, USA I72883 AALT 
194 Merriam, James  eft. nov. 1830Connecticut, USA I31996 AALT 
195 Graves, Margaret  24 apr. 1831Connecticut, USA I24851 AALT 
196 Bradley, Mary  31 mar. 1832Connecticut, USA I84872 AALT 
197 Brace, Captain Abel  20 jun. 1832Connecticut, USA I36273 AALT 
198 Brewster, Thomas  28 okt. 1832Connecticut, USA I15443 AALT 
199 Phelps, Charles E.  22 maj 1833Connecticut, USA I102585 AALT 
200 Pratt, Sarah  5 dec. 1833Connecticut, USA I94557 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.