Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 401 til 450 fra 494

«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
401 Burdick, Hattie E.  1862Connecticut, USA I29365 AALT 
402 Williams, Julia E.  9 mar. 1862Connecticut, USA I60916 AALT 
403 Hopkins, Emily A.  17 apr. 1862Connecticut, USA I63108 AALT 
404 Hogarty, Mary Emily  28 sep. 1863Connecticut, USA I96219 AALT 
405 Tanner, John E.  1864Connecticut, USA I29545 AALT 
406 Hough, Jennie Blakeslee  5 jan. 1864Connecticut, USA I63319 AALT 
407 Babcock, Phillip Sheridan  31 maj 1864Connecticut, USA I59032 AALT 
408 Pratt, Charles W  1868Connecticut, USA I86072 AALT 
409 Tanner, Edmund A.  1869Connecticut, USA I16671 AALT 
410 Stannis, Frank A.  23 maj 1869Connecticut, USA I115063 AALT 
411 Bidwell, Annie  1872Connecticut, USA I67321 AALT 
412 Tuttle, Julia Del  1872Connecticut, USA I63431 AALT 
413 Bidwell, Grove Sherman  1873Connecticut, USA I67343 AALT 
414 Honer, Martin Joseph  1875Connecticut, USA I62510 AALT 
415 Tanner, Walter C.  1875Connecticut, USA I17541 AALT 
416 Austin, Lucy R.  1878Connecticut, USA I63429 AALT 
417 Moore, Roberta E.  feb. 1878Connecticut, USA I65704 AALT 
418 Tuttle, Mary E  1879Connecticut, USA I67424 AALT 
419 Yale, Fred Thomas Jr  31 maj 1879Connecticut, USA I74418 AALT 
420 Ireland, Sarah Coe  1880Connecticut, USA I87938 AALT 
421 Munson, Henry Hallet  3 feb. 1880Connecticut, USA I78127 AALT 
422 Humphrey, Emma Louise  12 apr. 1881Connecticut, USA I67245 AALT 
423 Besse, Gertrude Louisa  22 apr. 1881Connecticut, USA I41038 AALT 
424 Birge, Louise M  1 apr. 1882Connecticut, USA I65403 AALT 
425 Griffin, Mary L.  ca. 1884Connecticut, USA I40557 AALT 
426 Tanner, Margaret E.  jan. 1884Connecticut, USA I17295 AALT 
427 Humphrey, Helen G  jun. 1884Connecticut, USA I67078 AALT 
428 Osborne, K Gertrude  9 sep. 1884Connecticut, USA I62269 AALT 
429 Burnham, Philip Theodore  1885Connecticut, USA I66771 AALT 
430 Mitchell, Basil K  1885Connecticut, USA I68128 AALT 
431 Fowler, Mabel E  jun. 1885Connecticut, USA I62993 AALT 
432 Yale, Son  1886Connecticut, USA I63080 AALT 
433 Bitgood, Mary Josephine  14 jun. 1886Connecticut, USA I84609 AALT 
434 Jennings, Ethel M.  okt. 1886Connecticut, USA I136261 AALT 
435 Brigham, Barbara L  nov. 1888Connecticut, USA I40190 AALT 
436 Fowler, Ethel B  dec. 1888Connecticut, USA I63046 AALT 
437 Norton, Willis Henry  14 jul. 1890Connecticut, USA I67151 AALT 
438 Bidwell, Lena Belle  jun. 1891Connecticut, USA I66901 AALT 
439 Schuetz, Anna Irene  22 feb. 1892Connecticut, USA I736 AAP 
440 Brewster, Ruth  14 jul. 1893Connecticut, USA I136309 AALT 
441 Griswald, Anita  1895Connecticut, USA I67278 AALT 
442 Judd, Alice Lucile  1895Connecticut, USA I66008 AALT 
443 Tanner, Marinda A.  jul. 1895Connecticut, USA I17358 AALT 
444 Bitgood, Rose Evelyn  1896Connecticut, USA I84546 AALT 
445 Fowler, Helen P  maj 1896Connecticut, USA I62766 AALT 
446 Hall, Mabel H  mar. 1898Connecticut, USA I63308 AALT 
447 Buren, Myron Van  5 jul. 1898Connecticut, USA I71903 AALT 
448 Teater, William A  ca. 1899Connecticut, USA I77460 AALT 
449 Goodenough, Dorothy  1900Connecticut, USA I65811 AALT 
450 Wallace, Barbara Manning  24 maj 1900Connecticut, USA I63050 AALT 

«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Næste»



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.