Mit slægtsforskingsprojekt.

Udskriv Tilføj bogmærke

Connecticut, USA



 


Træ: AAP

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383

Træ: AALT

Breddegrad: 41.5735, Længdegrad: -72.7383


Fødsel

Match 51 til 100 fra 494

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
51 Bitgood, Rose Evelyn  1896Connecticut, USA I84546 AALT 
52 Tanner, Marinda A.  jul. 1895Connecticut, USA I17358 AALT 
53 Judd, Alice Lucile  1895Connecticut, USA I66008 AALT 
54 Griswald, Anita  1895Connecticut, USA I67278 AALT 
55 Brewster, Ruth  14 jul. 1893Connecticut, USA I136309 AALT 
56 Schuetz, Anna Irene  22 feb. 1892Connecticut, USA I736 AAP 
57 Bidwell, Lena Belle  jun. 1891Connecticut, USA I66901 AALT 
58 Norton, Willis Henry  14 jul. 1890Connecticut, USA I67151 AALT 
59 Fowler, Ethel B  dec. 1888Connecticut, USA I63046 AALT 
60 Brigham, Barbara L  nov. 1888Connecticut, USA I40190 AALT 
61 Jennings, Ethel M.  okt. 1886Connecticut, USA I136261 AALT 
62 Bitgood, Mary Josephine  14 jun. 1886Connecticut, USA I84609 AALT 
63 Yale, Son  1886Connecticut, USA I63080 AALT 
64 Fowler, Mabel E  jun. 1885Connecticut, USA I62993 AALT 
65 Mitchell, Basil K  1885Connecticut, USA I68128 AALT 
66 Burnham, Philip Theodore  1885Connecticut, USA I66771 AALT 
67 Osborne, K Gertrude  9 sep. 1884Connecticut, USA I62269 AALT 
68 Humphrey, Helen G  jun. 1884Connecticut, USA I67078 AALT 
69 Tanner, Margaret E.  jan. 1884Connecticut, USA I17295 AALT 
70 Griffin, Mary L.  ca. 1884Connecticut, USA I40557 AALT 
71 Birge, Louise M  1 apr. 1882Connecticut, USA I65403 AALT 
72 Besse, Gertrude Louisa  22 apr. 1881Connecticut, USA I41038 AALT 
73 Humphrey, Emma Louise  12 apr. 1881Connecticut, USA I67245 AALT 
74 Munson, Henry Hallet  3 feb. 1880Connecticut, USA I78127 AALT 
75 Ireland, Sarah Coe  1880Connecticut, USA I87938 AALT 
76 Yale, Fred Thomas Jr  31 maj 1879Connecticut, USA I74418 AALT 
77 Tuttle, Mary E  1879Connecticut, USA I67424 AALT 
78 Moore, Roberta E.  feb. 1878Connecticut, USA I65704 AALT 
79 Austin, Lucy R.  1878Connecticut, USA I63429 AALT 
80 Tanner, Walter C.  1875Connecticut, USA I17541 AALT 
81 Honer, Martin Joseph  1875Connecticut, USA I62510 AALT 
82 Bidwell, Grove Sherman  1873Connecticut, USA I67343 AALT 
83 Tuttle, Julia Del  1872Connecticut, USA I63431 AALT 
84 Bidwell, Annie  1872Connecticut, USA I67321 AALT 
85 Stannis, Frank A.  23 maj 1869Connecticut, USA I115063 AALT 
86 Tanner, Edmund A.  1869Connecticut, USA I16671 AALT 
87 Pratt, Charles W  1868Connecticut, USA I86072 AALT 
88 Babcock, Phillip Sheridan  31 maj 1864Connecticut, USA I59032 AALT 
89 Hough, Jennie Blakeslee  5 jan. 1864Connecticut, USA I63319 AALT 
90 Tanner, John E.  1864Connecticut, USA I29545 AALT 
91 Hogarty, Mary Emily  28 sep. 1863Connecticut, USA I96219 AALT 
92 Hopkins, Emily A.  17 apr. 1862Connecticut, USA I63108 AALT 
93 Williams, Julia E.  9 mar. 1862Connecticut, USA I60916 AALT 
94 Burdick, Hattie E.  1862Connecticut, USA I29365 AALT 
95 Bitgood, Frederick Ellsworth  2 jul. 1861Connecticut, USA I96107 AALT 
96 Kettle, John Quincy  1861Connecticut, USA I96438 AALT 
97 Lane, Edith Frances  19 apr. 1860Connecticut, USA I62559 AALT 
98 Parmelee, Carrie Belle  feb. 1860Connecticut, USA I63074 AALT 
99 Pratt, Hannah  1860Connecticut, USA I83291 AALT 
100 Chappell  ca. 1860Connecticut, USA I120850 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Næste»



Død

Match 51 til 100 fra 276

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
51 Peck, Mary  13 aug. 1863Connecticut, USA I37531 AALT 
52 Burnham, Giles Geles  2 okt. 1858Connecticut, USA I46181 AALT 
53 Throop, William  13 jul. 1857Connecticut, USA I47288 AALT 
54 Pratt, Cynthia  29 aug. 1856Connecticut, USA I100615 AALT 
55 Tanner, Susan Mercelia  12 jun. 1856Connecticut, USA I13600 AALT 
56 Fenton, Augusta T  23 mar. 1855Connecticut, USA I115870 AALT 
57 Lynde, Mary Ann  19 dec. 1851Connecticut, USA I110296 AALT 
58 Hodge, Phoebe  eft. 1850Connecticut, USA I109 AALT 
59 Burrows, John Baldwin  3 mar. 1848Connecticut, USA I128372 AALT 
60 Smith, Nancy Ann  1848Connecticut, USA I35761 AALT 
61 Badger, Sarah  19 jul. 1847Connecticut, USA I29953 AALT 
62 Grover, Jerusha  20 feb. 1845Connecticut, USA I66860 AALT 
63 Linsley, Marietta  19 dec. 1842Connecticut, USA I25724 AALT 
64 Allen, Capt. Capt. Thomas  16 maj 1842Connecticut, USA I35825 AALT 
65 Sedgwick, Charles  30 mar. 1841Connecticut, USA I62530 AALT 
66 Babcock, Phebe  1841Connecticut, USA I95222 AALT 
67 Spencer, Hannah  13 apr. 1840Connecticut, USA I12763 AALT 
68 Goodrich, Joel  1840Connecticut, USA I49294 AALT 
69 Hull, Wyllys Deacon  8 maj 1839Connecticut, USA I117607 AALT 
70 Hemingway, Riley J.  17 feb. 1839Connecticut, USA I16476 AALT 
71 Taber, Amelia  14 jan. 1839Connecticut, USA I35904 AALT 
72 Sedgwick, Jane  1839Connecticut, USA I65586 AALT 
73 Starr, Fanny  20 aug. 1838Connecticut, USA I40336 AALT 
74 Partridge, William  2 okt. 1836Connecticut, USA I40293 AALT 
75 Lindsley, Abigail  9 feb. 1835Connecticut, USA I23881 AALT 
76 Coleman, Joseph  1835Connecticut, USA I60803 AALT 
77 Pratt, Sarah  5 dec. 1833Connecticut, USA I94557 AALT 
78 Phelps, Charles E.  22 maj 1833Connecticut, USA I102585 AALT 
79 Brewster, Thomas  28 okt. 1832Connecticut, USA I15443 AALT 
80 Brace, Captain Abel  20 jun. 1832Connecticut, USA I36273 AALT 
81 Bradley, Mary  31 mar. 1832Connecticut, USA I84872 AALT 
82 Graves, Margaret  24 apr. 1831Connecticut, USA I24851 AALT 
83 Merriam, James  eft. nov. 1830Connecticut, USA I31996 AALT 
84 Beckwith, Thomas  22 okt. 1829Connecticut, USA I72883 AALT 
85 Stanton, Cynthia L  15 jan. 1829Connecticut, USA I43963 AALT 
86 Stowell, Sarah  1829Connecticut, USA I93843 AALT 
87 Wilcox, Stephen  15 apr. 1828Connecticut, USA I117897 AALT 
88 Phelps, Sarah  30 nov. 1827Connecticut, USA I62257 AALT 
89 Seymour  1827Connecticut, USA I65635 AALT 
90 Everett, Hannah  3 aug. 1826Connecticut, USA I79102 AALT 
91 Judd, Mercy  27 apr. 1826Connecticut, USA I9048 AALT 
92 Mack, Sarah  mar. 1826Connecticut, USA I104277 AALT 
93 Hooker, Samuel  6 aug. 1825Connecticut, USA I143659 AALT 
94 Graves, Elder Josiah  24 jul. 1825Connecticut, USA I87110 AALT 
95 Ward, Rebecca  2 apr. 1825Connecticut, USA I42484 AALT 
96 Hubbard, Edmund  1825Connecticut, USA I94612 AALT 
97 De Cordova Y Benavides, Maria Joaquina Fernandez  1825Connecticut, USA I118476 AALT 
98 Crocker, Mary  1825Connecticut, USA I61329 AALT 
99 Atwater, Hannah  1825Connecticut, USA I51273 AALT 
100 Williams, Edward  5 jun. 1824Connecticut, USA I75283 AALT 

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»



Begravelse

Match 51 til 84 fra 84

«Forrige 1 2

   Efternavn, Fornavn    Begravelse    Person-ID   Træ 
51 Linsly, Ebenezer  Connecticut, USA I21252 AALT 
52 Kirtland, George  Connecticut, USA I63005 AALT 
53 Kirtland, Delight  Connecticut, USA I63101 AALT 
54 Kirtland, Clarissa  Connecticut, USA I63683 AALT 
55 Kirtland, Dr. Billius  Connecticut, USA I66967 AALT 
56 Kellogg, Margaret  Connecticut, USA I13013 AALT 
57 Judd, Katharine Welles  Connecticut, USA I65854 AALT 
58 Judd, George Morton  Connecticut, USA I65859 AALT 
59 Judd, Gardiner Wells  Connecticut, USA I68966 AALT 
60 Judd, Alice May  Connecticut, USA I65858 AALT 
61 Hull, Wyllys Deacon  Connecticut, USA I117607 AALT 
62 Hodge, Peggy  Connecticut, USA I9367 AALT 
63 Hickox, Joseph  Connecticut, USA I3222 AAP 
64 Hemingway, Samuel  Connecticut, USA I73261 AALT 
65 Hall, David M.  Connecticut, USA I63122 AALT 
66 Gardiner, Elizabeth  Connecticut, USA I61174 AALT 
67 Dodge, Daniel  Connecticut, USA I10638 AALT 
68 Davis, Sarah  Connecticut, USA I117804 AALT 
69 Cook, Mary F.  Connecticut, USA I63447 AALT 
70 Cook, Frances L.  Connecticut, USA I63430 AALT 
71 Cook, Catharine  Connecticut, USA I63274 AALT 
72 Conant, Hannah  Connecticut, USA I29429 AALT 
73 Bull, Cornelius W  Connecticut, USA I64209 AALT 
74 Brewster, William Mansfield  Connecticut, USA I12917 AALT 
75 Brewster, Hannah  Connecticut, USA I15621 AALT 
76 Brewster, Elisha  Connecticut, USA I136319 AALT 
77 Brewster, Abel  Connecticut, USA I12671 AALT 
78 Bissell, Abigail  Connecticut, USA I31426 AALT 
79 Birchard, Hannah  Connecticut, USA I72597 AALT 
80 Armstrong, Peletiah  Connecticut, USA I9148 AALT 
81 Adams, William  Connecticut, USA I11122 AALT 
82 Adams, James  Connecticut, USA I11085 AALT 
83 Abell, Mehitable  Connecticut, USA I134790 AALT 
84 Abell, Mehitable  Connecticut, USA I27075 AALT 

«Forrige 1 2



Ægteskab

Match 51 til 100 fra 101

«Forrige 1 2 3 Næste»

   Familie    Ægteskab    Familie-ID   Træ 
51 Loomis / Brewster  mar. 1806Connecticut, USA F30138 AALT 
52 Clark / Keeler  3 maj 1802Connecticut, USA F15771 AALT 
53 Merriam / Parker  1798Connecticut, USA F6762 AALT 
54 Flint / Hawes  1797Connecticut, USA F23791 AALT 
55 Beckwith / Fuller  ca. 1796Connecticut, USA F15518 AALT 
56 Smith / Burrows  6 mar. 1788Connecticut, USA F7446 AALT 
57 Andros / Sampson  1779Connecticut, USA F30509 AALT 
58 Hodge / Elwell  nov. 1778Connecticut, USA F287 AALT 
59 Stanton / Palmer  ca. 1778Connecticut, USA F2120 AALT 
60 Lovegrove / Fillmore  1775Connecticut, USA F6534 AALT 
61 Rudd / Lathrop  1772Connecticut, USA F3705 AALT 
62 Drake / Sadd  ca. 1770Connecticut, USA F9733 AALT 
63 Stoughton / Ellsworth  1769Connecticut, USA F10588 AALT 
64 Paine / Ellsworth  1769Connecticut, USA F3899 AALT 
65 Hayes / Roland  1769Connecticut, USA F18105 AALT 
66 Dodge / Gardiner  1769Connecticut, USA F11527 AALT 
67 Kellogg / Phelps  1766Connecticut, USA F24022 AALT 
68 Belty / Carpenter  1761Connecticut, USA F7515 AALT 
69 Phelps / Denison  10 sep. 1757Connecticut, USA F16033 AALT 
70 Dewolf / Little  1756Connecticut, USA F7944 AALT 
71 Bixby / Hammond  ca. 1753Connecticut, USA F181 AALT 
72 Brewster / Sweatland  30 mar. 1749Connecticut, USA F24047 AALT 
73 Mix / Goodwin  1747Connecticut, USA F15033 AALT 
74 Moulthrop / Way  22 jun. 1745Connecticut, USA F284 AALT 
75 Sedgwick / Tyler  1744Connecticut, USA F12021 AALT 
76 Stevens / Hodges  5 dec. 1742Connecticut, USA F330 AALT 
77 Burnham / Williams  27 maj 1738Connecticut, USA F4513 AALT 
78 Fuller / Beckwith  ca. 1737Connecticut, USA F15553 AALT 
79 Bidwell / Gilman  1733Connecticut, USA F2179 AALT 
80 Fillmore / Carrier  1732Connecticut, USA F1906 AALT 
81 Woodruff / Mason  3 dec. 1730Connecticut, USA F16348 AALT 
82 Spencer / Clark  1730Connecticut, USA F4734 AALT 
83 Beckwith / Harvey  ca. 1730Connecticut, USA F15448 AALT 
84 Porter / Snow  26 dec. 1728Connecticut, USA F1242 AALT 
85 Weeks / Armstrong  1726Connecticut, USA F3909 AALT 
86 Hodge / Russell  1725Connecticut, USA F269 AALT 
87 Dorman / Sperry  23 apr. 1724Connecticut, USA F811 AALT 
88 Barnes / Christophers  ca. 1720Connecticut, USA F686 AAP 
89 Stevens / Peck  1714Connecticut, USA F229 AALT 
90 Hemingway / Talmadge  11 nov. 1713Connecticut, USA F2881 AALT 
91 Filleau / Stevens  29 dec. 1703Connecticut, USA F18242 AALT 
92 Spencer / Booth  28 feb. 1699Connecticut, USA F4009 AALT 
93 Loomis / Cook  eft. 1691Connecticut, USA F11554 AALT 
94 Case / Moore  3 nov. 1691Connecticut, USA F10972 AALT 
95 Hooker / Hamlin  28 jun. 1687Connecticut, USA F32185 AALT 
96 Thompson / Lathrop  1683Connecticut, USA F15965 AALT 
97 Stanton / Dennison  16 jun. 1680Connecticut, USA F8615 AALT 
98 Phelps / Randall  30 nov. 1648Connecticut, USA F26639 AALT 
99 Phelps / Wilson  4 jun. 1646Connecticut, USA F21042 AALT 
100 Hull / Foster  Connecticut, USA F24860 AALT 

«Forrige 1 2 3 Næste»



Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.